Strange DNA
Merging paper sources with DNA to Ancient Roots to Ireland, Scotland & Scandinavia through Europe to Armenia.
First Name
Last Name
[Advanced Search]
[Surnames]
Home
Search
Login
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
What's New
Most Wanted
Reports
Dates
Calendar
Cemeteries
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Recordings
Videos
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Bookmarks
Contact Us
Print
Bookmark
Search
•
Advanced Search
•
Search Families
•
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
John Strange
1490 - 1572 (82 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
John Strange
[1]
b. 1490 d. 1572
Elizabeth
2
Thomas Strange
[1.1]
b. 1522 d. 1589
Mary Tucker
3
Symon Strange
[1.1.1]
b. 1550
Eleanor Saunders
4
John Strange
[1.1.1.1]
b. 1 Jan 1580 d. 1642
Elizabeth Hollee
b. 1586
5
John X Strange, I
[1.1.1.1.1]
b. 6 Feb 1621 d. 1686
Elizabeth Mitchell
b. 1632 d. 1662
6
John Strange, II
[1.1.1.1.1.1]
b. 1662 d. 1730
Elizabeth
7
John “Alloway’s” Strange, III
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 1700 d. 1742
Ann or Galloway Alloway
8
John Alloway of Fluvanna, Oak Hill Strange, IV
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 15 Jan 1727 d. 1 Sep 1811
Anne [Mildred] Mitchell
b. 3 Jan 1728 d. 1781
9
Abner Alloway Strange, of Elk River
[1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 14 Mar 1761 d. 27 Aug 1835
Elizabeth Mitchell
b. 14 Oct 1756 d. 22 Jan 1803
10
Nancy Ann Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1797
+
Charles Mitchell Bernard
b. 11 Feb 1788
10
Martha M. Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 4 Sep 1799
+
Flanagan
10
Edward Saunders ? Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. Abt 1785
10
Judith Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
d. Bef 1834
10
Mildred A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
d. Bef 1834
10
Thomas M. A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6]
d. 18 Dec 1855
10
John Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7]
10
Eleanore Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 8 Feb 1782
10
Gideon M. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 1783
10
Abner Alloway Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10]
b. 1788
10
Rebecca Ann Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.11]
b. 1800
9
Abraham Alloway Strange, of Upper Yadkin
[1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1746 d. 1815
Mary Molly Moore
b. 1758 d. 10 Nov 1842
10
Nancy Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 1779 d. Aft 1843
Solomon Israel
b. 1774
11
UNK Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1]
11
Rebecca Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2]
11
Michael Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 1802
11
Abraham Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4]
b. 1808
+
Polly? Polly
11
Isom Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5]
b. 1812
11
Pleasant Walker Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6]
b. 16 Mar 1816 d. 28 Feb 1901
+
Sarah E. Wolfe
11
George Nelson Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7]
b. 8 Dec 1819 d. 1890
Indiana Lance
b. 4 Aug 1820 d. Abt 1902
12
Charles M. Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7.1]
b. Abt 1843
12
Missouri Alice Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7.2]
b. Abt 1845 d. Dec 1879 [
=>
]
12
Elizabeth Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7.3]
b. Abt 1849
12
Pleasant Walker Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7.4]
b. Abt 1851
12
Evelyn Pirreva Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7.5]
b. Abt 1855
12
Benjamin Charleton Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7.6]
b. Abt 1860
12
Arthur Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7.7]
b. Abt 1863
12
Engleton Jospeh Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7.8]
b. Abt 1865
11
Felix Walker Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.8]
b. 1820
+
Nancy
b. 1818
10
Archelaus Alloway Strange, of Crocus Creek
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 12 Jul 1780 d. 23 Oct 1852
Elizabeth Coffey
b. 10 Jan 1782 d. 16 Sep 1853
11
John Claiborne Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1]
b. 4 Nov 1804 d. 1865
Sally Walkup
12
Jack Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.1]
12
Arthur Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.2]
12
Butler Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.3]
11
William Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2]
b. 11 Dec 1805 d. 20 Mar 1845
Demarius A. Davis
12
Lucillla Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.1]
b. 1829
12
Archelaus Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.2]
b. 1831 d. 15 Nov 1898 [
=>
]
12
EA Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.3]
b. 1835
12
William BA Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.4]
b. 1837
12
James L. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.5]
b. 23 Oct 1839 [
=>
]
12
James A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.6]
12
Marva GB Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2.7]
b. 1845 [
=>
]
11
Abraham A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3]
b. 3 Mar 1808 d. 10 Aug 1866
Elizabeth Morrison
b. 1811 d. 1867
12
Mary L. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.1]
b. 8 Mar 1834 d. 9 Apr 1855
12
John K. A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.2]
b. 8 Mar 1834 d. 29 Apr 1901 [
=>
]
12
Elizabeth F. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.3]
b. 8 Jun 1838
12
Martha Jane Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.4]
b. 11 Jan 1841 d. 14 Jul 1923
12
Archelaus Clayborne Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.5]
b. 1842 d. 1909 [
=>
]
12
Lucy Ann Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.6]
b. 5 Jan 1845
12
William O. Butler Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.7]
b. 8 Sep 1848
12
Sarah D. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.8]
b. 13 Jan 1854
11
Lewis Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4]
b. 19 Mar 1810 d. 10 Jan 1886
Isabel Jane Biggs
b. 10 Sep 1820 d. 2 Jan 1903
12
James Knox Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.1]
b. 22 Sep 1844
12
Mary Virginia Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.2]
b. 4 Nov 1846
12
Elizabeth Jane Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.3]
b. 3 Mar 1850 [
=>
]
12
Lewis Wilson Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.4]
b. 19 Jan 1853 [
=>
]
12
Sarah Isabel Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.5]
b. 1855
12
Timothy Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.6]
b. 1861
12
Thomas H. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.7]
b. 1861
11
Archelaus Alloway Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5]
b. 13 Sep 1812 d. 26 May 1884
Celia Ann Miller
12
Vera Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.1]
12
Isaac Hardin Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.2]
b. 30 Mar 1837
12
Captain James Logan Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.3]
b. 1838 [
=>
]
12
Amanda C. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.4]
b. 9 Feb 1840
12
Elmore Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.5]
b. 9 Feb 1840
12
Shelby Winston A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.6]
b. 8 Dec 1842 [
=>
]
12
Elizabeth Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.7]
b. 26 Nov 1844
12
Dr. Archelaus A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.8]
b. 23 Nov 1846 [
=>
]
12
Dr. Winston A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.9]
b. 1847
12
Anna Maria Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.10]
b. 11 Apr 1849
12
Elizabeth Eliza Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.11]
b. 11 Apr 1852
12
Commodore A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.12]
b. 1854 [
=>
]
12
Louvenia M. Vienna Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.13]
b. 1856
12
Mary Victoria Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.14]
b. 1858
11
Allen Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6]
b. 18 Dec 1813
+
Livonia Cassida
Nancy M. Parish
12
Madison A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6.1]
b. 16 Feb 1844
12
Marietta A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6.2]
b. 10 Sep 1845
12
ELisha Lewis A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6.3]
b. 10 Sep 1847
12
Elizabeth A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6.4]
b. 24 Sep 1849
12
Volia A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6.5]
b. 10 Sep 1852
12
James A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6.6]
b. 10 Nov 1854
12
Henry Clay Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6.7]
b. 16 Nov 1856 [
=>
]
12
Mary A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6.8]
b. 16 Feb 1859
12
Nathaniel Lyon A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6.9]
b. 18 Apr 1861
12
Analiza A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6.10]
b. 10 Jul 1863
12
Nancy A. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6.11]
b. 15 Apr 1865
11
Mary Viamby Polly Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7]
b. 31 Dec 1814
+
John L. Thomas, Jr.
11
William Levi A. ??? Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8]
b. 1 Apr 1817 d. 3 Dec 1882
Elizabeth Robertson
12
Van Buren Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.1]
b. 24 Nov 1842 d. 1910 [
=>
]
12
George Alford Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.2]
b. 9 Apr 1844
12
James Polk Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.3]
b. 1844
12
Houston Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.4]
b. 6 Apr 1847
12
California Callie Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.5]
b. 20 Mar 1849
12
Dora Ann Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.6]
b. 12 Apr 1851
12
Frank Pierce Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.7]
b. 15 May 1853
12
Sarah Ellen Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.8]
b. 17 Oct 1859
12
WIlliam Levi Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.9]
b. 26 Jun 1862 [
=>
]
11
Larkin Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9]
b. 9 May 1819 d. 25 Aug 1884
Mary Ann Simpson
12
Shelby Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9.1]
b. 25 Feb 1845
12
Sarah Elizabeth Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9.2]
b. 8 Jun 1847
12
Samuel Archelaus Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9.3]
b. 21 Jan 1850 [
=>
]
12
Joseph H. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9.4]
b. 11 Feb 1852 [
=>
]
12
Larkin Chrisman Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9.5]
b. 3 Aug 1854 [
=>
]
12
Asa P. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9.6]
b. 9 Nov 1856
12
Benjamin F. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9.7]
b. 8 Aug 1859 [
=>
]
12
Molly B. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9.8]
b. 14 Oct 1863
12
James Austin Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9.9]
b. 12 Feb 1867
11
Winston Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.10]
b. 13 Mar 1821 d. Jan 1900
Margaret Jane Meadows
12
Emma Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.10.1]
b. 10 Mar 1852
+
Mildred Walkup
11
Elizabeth Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.11]
b. Apr 1823
William Peter Walkup
12
Taylor Walkup
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.11.1]
11
Ellen Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.12]
b. 1825
10
John Walker S. Alloway of Jennings & Jasper Dropped Strange - Used ALLOWAY, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 27 Sep 1781 d. 2 May 1863
Elizabeth Waters
11
Nancy Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.1]
b. 19 Jan 1806
+
David Blue
+
Joseph Cooper
11
Sarah Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.2]
b. 1808
Jane Curtis
11
john Thomas Alloway Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3]
b. 1813
Francis Ann Norris
12
Orville Norris Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.1]
b. Jun 1836
12
Elizabeth R. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.2]
b. Abt 1838
12
Charles N. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.3]
b. Jan 1841
12
Zenith Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.4]
b. Abt 1842
12
John J. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.5]
b. Abt 1845
11
Alfred Alloway Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4]
b. 1817
+
Nancy
b. 1820
Lucy Johns
b. 30 Aug 1820
12
Allen Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.1]
b. 1837 [
=>
]
12
Sarah Jane Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.2]
b. Abt 1838
12
John Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3]
b. Abt 1839
12
Eliza Ann Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4]
b. 1841
12
Lafayette Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.5]
b. 27 Feb 1844
12
Emma Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.6]
b. Abt 1846
+
Susan White
Elizabeth Herring
12
WIlliam Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.7]
b. 10 Jan 1867
12
Edward Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.8]
b. 1868
12
Adella Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.9]
b. 1869
12
Emmons Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.10]
b. Abt 1874
11
Allen Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.5]
b. 1817
Martha Dinsmore
12
Peter Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.5.1]
b. 1839 d. Aug 1864 [
=>
]
11
Susannah Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6]
b. 1820
Lewis Herring
12
Noah Herring
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6.1]
12
Elias Herring
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6.2]
12
Ezra Herring
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6.3]
12
Abel Herring
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6.4]
12
John Herring
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6.5]
11
Caroline Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.7]
b. 1822
+
Hasten Luallen
11
Abijah Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.8]
b. 16 Jun 1824 d. 3 Dec 1874
Malinda Arnspiger
12
Hester Ann Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.8.1]
b. 30 Oct 1847
12
George Smith Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.8.2]
12
Mary Bell Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.8.3]
12
Sarah Ellen Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.8.4]
[
=>
]
12
Jay B. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.8.5]
[
=>
]
12
Abijah Bige Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.8.6]
b. 8 Apr 1859 d. 10 Feb 1932
12
Emma Blanche Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.8.7]
b. 8 Jul 1863 d. 10 Feb 1931 [
=>
]
11
Abisha Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.9]
b. 16 Jun 1824 d. 10 Nov 1863
Adeline Francis Chambers
12
Mary Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.9.1]
b. 1844
12
Sarah Jane Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.9.2]
b. 7 May 1846
12
John Wesley Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.9.3]
b. 9 May 1848
12
James Thomas Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.9.4]
b. 15 Aug 1850
12
George Washington Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.9.5]
b. 2 Oct 1852
12
Winfield S. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.9.6]
b. 1855
Francis Sarah Reed
b. 1819
12
Ellen Reed Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.9.7]
b. 2 Oct 1852
12
Charles Freemont Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.9.8]
b. 24 Mar 1857
12
Abisha Annis Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.9.9]
b. 16 May 1859
12
Emma Frances Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.9.10]
b. 17 Sep 1861
12
Ulysses S. Grant Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.9.11]
b. 21 May 1863
11
Nelson Dropped Strange - Used ALLOWAY, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.10]
b. Abt 1826 d. Aft 1885
Martha Baker
b. Abt 1830
12
Shelby Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.10.1]
b. Abt 1850 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.10.2]
b. 1851
12
John Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.10.3]
b. 1853
12
Jane Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.10.4]
b. 1855
12
Nancy F. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.10.5]
b. 1857
12
Nelson Dropped Strange - Used ALLOWAY, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.10.6]
b. 1859
12
Martha M. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.10.7]
b. Oct 1861
12
WIlliam Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.10.8]
b. 10 Apr 1863 [
=>
]
12
Sarah Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.10.9]
b. Abt 1865
12
Ralph Pellow Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.10.10]
b. 3 Jun 1867 [
=>
]
12
Dora Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.10.11]
b. 24 Aug 1869
12
Edna Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.10.12]
b. 9 Apr 1880
Anna Mary Barns
b. Abt 1791
11
Amanda Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.11]
+
John McClure
11
Alabama Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.12]
11
ELizabeth Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.13]
+
William Parker
+
Joseph Adam Dooley
10
Wilson Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 1784 d. Bef 28 Jun 1843
10
Judy Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 1786 d. Abt 1819
+
Isom Israel
10
Elizabeth Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 25 May 1787 d. 29 Jul 1856
+
Johnson
10
Susannah Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7]
b. 1788 d. Bef 1843
+
Coffey
10
Hannah S. Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8]
b. 13 Feb 1790 d. 14 Feb 1871
+
Coffey
10
Abraham T. Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.9]
b. 1792 d. Sep 1870
10
William Alloway *no kids Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.10]
b. 1794 d. 1843
10
Polly Alloway *no kids Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.11]
b. 1796 d. Bef 1847
10
Nelson Alloway Strange, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.12]
b. 1799 d. 29 Jul 1842
10
WIlson Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.13]
b. 1784
Sally
11
Hannah Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.1]
+
John Bonhill
11
Elizabeth Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.2]
+
Titus Pendergrass
11
John Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.3]
11
Albert Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.4]
11
Nelson Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.5]
11
Mary Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.6]
+
Job Pendergrass
11
WIlliam A. Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.7]
11
Nancy Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.8]
+
Shadrick Raby
10
Judy Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.14]
b. 1785
Isom Israel
11
Polly Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.14.1]
b. 1801 d. 1804
11
Mahala Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.14.2]
b. 1802
+
Phillip Ware
11
Archibald Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.14.3]
b. 1805
+
Amy Parr
11
Michael Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.14.4]
b. 1810
+
Mary Jean DuBois
11
Jesse Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.14.5]
b. 1815
+
Sarah Sallie Price
11
UNK Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.14.6]
b. 1817
11
Nelson Israel
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.14.7]
b. 1819
+
Rachel Israel
10
Elizabeth Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.15]
b. 25 May 1787 d. 29 Jul 1856
+
John Johnson
10
Susannah Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.16]
b. 1788
+
William COFFEY
10
Hannah Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.17]
b. 18 Feb 1790
James Coffey
11
Archelaus Coffey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.17.1]
11
Sally Coffey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.17.2]
11
Abraham Coffey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.17.3]
11
Mary Coffey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.17.4]
11
Riley Coffey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.17.5]
11
John Davidson Coffey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.17.6]
11
Elvira Ann Coffey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.17.7]
10
Abraham T. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.18]
b. 1792 d. 1870
Mary Loving
11
Lora Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.18.1]
+
Washington Furgeson
11
John F. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.18.2]
b. Abt 1813
+
Jency Jane Lafarve
Malinda Goodwin
12
John W. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.18.2.1]
12
James Perry Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.18.2.2]
12
Nancy Matilda Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.18.2.3]
11
Mary D. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.18.3]
11
Nelson Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.18.4]
11
Azor Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.18.5]
11
James T. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.18.6]
11
Angeline T. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.18.7]
11
Abraham T. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.18.8]
b. 1832
10
William Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.19]
b. 1796
10
Polley Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.20]
b. 1797
10
Nelson Alloway Strange, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.21]
b. 25 Feb 1799
+
Susan Corpening
+
Ann Corpening
9
Archelaus S. “Archer” Alloway Strange, of Boone
[1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 1748 d. 20 Aug 1808
Elizabeth Vannerson
b. 1753
10
John S. Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 22 Sep 1782 d. 2 May 1863
9
Mary “Molly” Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1752 d. 1811
+
Bell
9
Rebecca Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 1754 d. 14 Apr 1841
+
Sanders
9
John Alloway “Jesse” Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 1755 d. 1800
9
Martha Patsey Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 22 Sep 1756 d. 13 Sep 1831
9
Francis A. “Grandby” Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 1764 d. 19 Feb 1851
Benjamin Bowles
10
Rebecca Mitchell Bowles
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.1]
10
Jesse T. Bowles
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.2]
11
Malvina Virginia Bowles
[1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.1]
Mildred Ann “Milly” Barnett
9
William Clayburn Alloway Strange, of Rock Rest
[1.1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 23 Jul 1783 d. 30 Aug 1841
Mary Gregory Perkins
b. 12 Jul 1786 d. 29 Sep 1845
10
Archer Perkins Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.1]
b. 12 Mar 1808
10
John B. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.2]
b. 16 Aug 1809 d. 26 Apr 1888
10
Mildred Ann Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.3]
b. 1 Aug 1811 d. 1887
+
William J. Key
d. 1883
10
Mary Reed Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.4]
b. 13 Jun 1813 d. 1882
Wingfield M. Cosby
b. 1809 d. 1864
11
Clara Cosby
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.4.1]
Robert C. Ely
12
Mary Reed
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.4.1.1]
11
Sally Cosby
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.4.2]
James F. Tull
12
Clara Tull
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.4.2.1]
11
Mary Claiborne Cosby
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.4.3]
John Blackwell Hale
12
Mary Elizabeth Hale
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.4.3.1]
10
Gideon Elijah M. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.5]
b. Jun 1815 d. 6 May 1909
Clara Hickman
11
Miller Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.1]
d. 1933
+
Martha Phipps
11
Gideon Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.2]
b. 1843
12
Mary May Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.2.1]
12
UNK Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.2.2]
12
Dr. Shelby Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.2.3]
b. 1872
12
Bess Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.2.4]
b. 1874
12
Calranell Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.2.5]
b. 1884 [
=>
]
10
Sarah E. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.6]
b. 25 Jun 1817
+
William A. Landrum
10
Lucy M. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.7]
b. 25 Nov 1819
+
John Herndon
10
William George Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8]
b. 22 Apr 1823 d. 21 Nov 1887
Mary Ann Seay
b. 25 Feb 1828 d. 21 Feb 1902
11
William C. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.1]
b. 1848 d. 1871
11
Alice Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.2]
b. 1849
Henry S. Holland
12
Mary Alice Holland
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.2.1]
12
Bessie Holland
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.2.2]
12
Russell Holland
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.2.3]
12
Henry Holland
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.2.4]
12
Ruth Holland
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.2.5]
12
Lille Holland
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.2.6]
11
Betty Loving Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.3]
b. 28 Aug 1850 d. 6 Sep 1913
George Payne Seay
b. 9 Feb 1844 d. 3 Mar 1909
12
George Bledsoe Seay
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.3.1]
b. 4 Oct 1881 d. 5 Oct 1964
11
Peyton Austin Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.4]
b. 17 Sep 1851 d. 16 Jun 1934
+
Mary Lou Perkins Hukstep
b. 28 Apr 1851 d. 28 Aug 1928
Clara A. Thomas
b. 26 Aug 1853 d. 8 May 1902
12
Bertha Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.4.1]
[
=>
]
12
Mary Lou Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.4.2]
12
Eva Claiborne Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.4.3]
12
Lena Gertrude Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.4.4]
12
Alice May Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.4.5]
b. 1884 d. 1982 [
=>
]
12
William Archer Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.4.6]
b. 29 Jul 1889 d. 11 Apr 1945
12
Eugene Peyton Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.4.7]
b. 17 Feb 1895 d. 4 Apr 1925
11
Robert Lee Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.5]
b. 1862 d. 1923
Kate Thomas
12
Bernice Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.5.1]
12
Catherine Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.5.2]
12
Robert Lee Shine Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.5.3]
12
Virginia Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.8.5.4]
10
Eurebia Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9.9]
b. 15 Sep 1825
+
Charles Perkins
9
George Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10]
b. 1786 d. 1837
9
Sarah Maria “Sally” Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11]
b. 5 Apr 1788 d. 4 Aug 1852
9
Col. Gideon Alloway Strange, I - of Dog Point
[1.1.1.1.1.1.1.1.12]
b. 7 Mar 1793 d. 23 Feb 1838
Harriet Magruder
d. 1829
10
Edward Magruder Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.1]
b. 1817
Rose Whitney
11
Helen Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.1.1]
b. 1829
10
James Magruder Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.2]
b. 8 Aug 1818
Harriet P. Mayo
11
William Mayo Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.2.1]
b. 8 May 1844
+
Mary Lucy Powell
11
Harriet Carrington Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.2.2]
b. 1846
11
James Magruder Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.2.3]
b. 1847
11
John Bowie Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.2.4]
b. 1849
11
Harriet Catherine Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.2.5]
b. 24 Jan 1852
11
Sallie Willie Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.2.6]
b. 6 Apr 1855
11
Anne Edmonia Annie Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.2.7]
b. 28 Dec 1858
11
Josephine Epps Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.2.8]
b. 29 Nov 1861
10
Sarah W. Willie Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.3]
b. 1819 d. Mar 1844
+
William Stockton
10
Ann Mildred Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.4]
b. 1821
James Laurence Carrington
11
Anna Mildred Carrington
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.4.1]
+
J.M. Benson
10
Harriet V. Hattie Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.5]
b. Feb 1822 d. 13 Aug 1859
Thomas Harrison Tutwiler
11
Edward Magruder Tutwiler
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.5.1]
11
2 Tutwiler
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.5.2]
11
3 Tutwiler
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.5.3]
10
Col. John Bouie Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.6]
b. 1823 d. 1862
Martha Agnes Gaines
b. 1830 d. 1887
11
H.B. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.6.1]
b. 1852 d. 1916
11
Agnes Gwathney Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.6.2]
b. 1852
+
Southal
11
John Agnes Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.6.3]
b. 1856 d. 1857
11
W.T. Willoughby Temple Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.6.4]
b. 6 Sep 1860 d. 1917
11
John Bowie Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.6.5]
11
Gideon * Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.6.6]
10
Gideon Alloway Strange, II
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7]
b. 1825 d. 1899
Catherine Ann Marion Mayo
11
Ruth Carrington Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.1]
+
Rev. George Walker Watkins
11
Fannie Bouie Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.2]
11
Harriet Mayo Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.3]
+
Miller
11
William Howard Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.4]
Maude Rainey
12
Walter Griggs Strange, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.4.1]
[
=>
]
12
Edna Marian Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.4.2]
12
Edward Duke Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.4.3]
12
Hattie C. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.4.4]
12
Alice Bouie Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.4.5]
12
WIlliam Melvin Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.4.6]
b. 1899 [
=>
]
12
Paul Howard Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.4.7]
12
John Magruder Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.4.8]
12
Frances Elizabeth Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.4.9]
11
Sarah Magruder Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.5]
11
Edna G. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.6]
b. 1871
11
Catherine Marion Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.7]
b. 1871
+
John Shepard Rainey
11
GIdeon Alloway Strange, III
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.8]
b. 1866 d. 1956
Eva Garrett Shackleford
12
Gideon Alloway Strange, IV
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.8.1]
b. 19 Feb 1894 d. 11 Nov 1947 [
=>
]
12
R. May Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.8.2]
b. 1896
12
Virginia Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.8.3]
b. 1898
12
Edith Estelle Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.8.4]
b. 1900
12
Hattie Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.8.5]
b. 1902
12
Evaline Evelyn Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.8.6]
b. 1904
12
George S. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.8.7]
b. 1906
11
Virginia L. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.7.9]
b. 1868
+
David Owens
10
Mary Elizabeth Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.8]
b. 15 Jan 1829 d. 12 Nov 1898
+
John W. Chewning
Mary B. Gay
b. 1794 d. 1879
10
Charles Windham Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.9]
10
Henry Erskin Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.10]
10
Frances B. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.11]
+
R.H. Catlette
10
Lizzie E. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.12]
10
William Gay Alloway Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.13]
b. 1833 d. 1877
10
Agatha Estell Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.14]
10
Caroline Scott Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12.15]
+
William M. Allen
6
Mitchell Strange
[1.1.1.1.1.2]
b. 1660 d. 20 Apr 1717
+
Elizabeth
6
Benjamin Strange
[1.1.1.1.1.3]
b. 1650 d. 1675
6
Henry Strange
[1.1.1.1.1.4]
b. 1652 d. 1710
6
Elizabeth Strange
[1.1.1.1.1.5]
b. 1654
6
Anne Strange
[1.1.1.1.1.6]
b. 1656
+
Robert Hughes
6
Margaret Strange
[1.1.1.1.1.7]
b. 1659
6
Amos Strange
[1.1.1.1.1.8]
Phebe Morris
b. 30 Aug 1642 d. 1710
6
Alexander Strange
[1.1.1.1.1.9]
b. 1665 d. 2 Sep 1725
Anne Sammis
7
Henry S. Strange
[1.1.1.1.1.9.1]
b. 1695 d. 1745
Mary Liptrop
b. 1695 d. 1750
8
Edmond Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1]
b. 9 Jan 1729 d. 1800
Mary Spencer
9
Amos Alexander Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1]
b. 1 Nov 1759 d. 1 Jun 1842
Frances Bailey
b. Oct 1774
10
William Bradford Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1]
b. 8 Dec 1791 d. 22 Mar 1848
Mary L. Walker Fowler
b. 8 May 1797 d. 1868
11
David William Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1.1]
b. 1815 d. 1873
Elizabeth Wood
b. 1814 d. Aug 1860
12
Captain William Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1.1.1]
b. 17 Dec 1836 d. 28 May 1901 [
=>
]
12
Martha J. Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1.1.2]
12
James D. Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1.1.3]
Susan
b. Abt 1825
12
Mary E. Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1.1.4]
12
Isabel Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1.1.5]
11
John Anderson Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1.2]
b. 11 Sep 1824 d. 17 Mar 1895
Fidello J. Grisham
b. 1826 d. 1894
12
Alexander Taylor Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.1.2.1]
b. 6 Jul 1850 d. 3 Feb 1932 [
=>
]
10
Little Berry Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.2]
b. 2 Jul 1807 d. 27 May 1888
10
Mary E. Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.3]
10
Marshall Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.4]
10
Rebecah Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.5]
10
Rachel Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.6]
10
Permela Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.7]
10
Amos Bradford Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.8]
b. 1 Nov 1789 d. 1875
Mary Ann Henderson
11
Edward J. B. Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.8.1]
b. 1839 d. 1916
Mary Elizabeth McClendon
d. 1885
12
Amos Bradford Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.8.1.1]
b. 13 Jul 1875 d. 1 Sep 1936 [
=>
]
11
Marshall Crumby Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.8.2]
12
John Ervin Luther Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.8.2.1]
[
=>
]
11
William Berry Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.8.3]
12
Samuel Lusers Strange
[1.1.1.1.1.9.1.1.1.8.3.1]
[
=>
]
8
Mitchell Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2]
b. 11 Aug 1726 d. 1788
Elizabeth Tucker
b. Abt 1725
9
Michael Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.1]
b. 1748
Mary Ellis
10
Susanna Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.1.1]
10
Edmond Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.1.2]
10
*Stephen Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.1.3]
b. 1766 d. 1830
11
*Samuel Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.1.3.1]
b. 1 Jan 1792 d. 1886
Elizabeth Davidson
b. 1792
12
*Mitchell Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.1.3.1.1]
b. 1824 d. 14 Jun 1900 [
=>
]
12
*Elizabeth Betsey Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.1.3.1.2]
b. 1821 d. 1899 [
=>
]
12
^Mary Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.1.3.1.3]
b. 1829 d. 1876 [
=>
]
12
Sarah Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.1.3.1.4]
12
David Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.1.3.1.5]
12
Nancy Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.1.3.1.6]
11
Benjamin C. Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.1.3.2]
b. 1786 d. 1848
11
? Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.1.3.3]
11
? Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.1.3.4]
9
Littleberry Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.2]
b. 1758
9
Isham Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.3]
9
Rachel Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.4]
9
Ephriam Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.5]
9
Susanna Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.6]
9
Edmond Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.7]
9
Henry Strange
[1.1.1.1.1.9.1.2.8]
8
Elizabeth Strange
[1.1.1.1.1.9.1.3]
8
James Strange
[1.1.1.1.1.9.1.4]
8
Jane Strange
[1.1.1.1.1.9.1.5]
8
Henry Strange, II
[1.1.1.1.1.9.1.6]
8
Gideon Strange
[1.1.1.1.1.9.1.7]
7
Mitchell Strange
[1.1.1.1.1.9.2]
b. 22 Oct 1693 d. Abt 1711
7
Judith Strange
[1.1.1.1.1.9.3]
b. 16 Oct 1696
7
Michael Strange
[1.1.1.1.1.9.4]
b. 22 Dec 1698
7
Elizabeth Strange
[1.1.1.1.1.9.5]
b. 5 Apr 1702
7
Anne Strange
[1.1.1.1.1.9.6]
b. 11 Jun 1704
7
Robert Strange
[1.1.1.1.1.9.7]
b. 5 Jan 1707
7
Elinor Strange
[1.1.1.1.1.9.8]
b. 2 Jan 1709
7
Agnes Strange
[1.1.1.1.1.9.9]
Anne Jenkins
7
Alexander Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.9.10]
b. 18 Oct 1691
Sarah
8
Joseph Strange, Sr.
[1.1.1.1.1.9.10.1]
b. 14 Mar 1716 d. 1749
9
Joseph of Albermarle Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.9.10.1.1]
b. 1736 d. 1782
10
James E. Strange, Sr.
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.1]
b. 1760 d. 1835
11
James Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.1.1]
b. 1785 d. 1850
Frances Fanny Fancy Miller Milly
12
Jinittie Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.1.1.1]
b. 1815 d. 1853
10
David of Albermarle Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2]
b. 1764 d. 1841
Eliza Elizabeth Eubank
11
Sarah Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.1]
b. 1786
+
Benjamin Hunt
11
Hudson David Jr or Sr Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.2]
b. 1790 d. 1850
Sarah Sally Hamner
12
David Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.2.1]
b. 1813
12
Reuben C. Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.2.2]
b. 1815 [
=>
]
12
John Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.2.3]
b. 1818 [
=>
]
12
Tucker Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.2.4]
b. 1825 [
=>
]
11
Elizabeth Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.3]
b. 1792 d. 1808
+
Powell
11
John Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.4]
b. 1795
+
Frances Cloar
11
Mary Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.5]
b. 1797
+
Micajah Ellerton
11
George E. Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.6]
b. 1798
+
Mary Watson
11
Melinda Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.7]
b. 1800
+
Edward Wingfield
11
Elizabeth II Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.8]
11
UNK Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.9]
11
Sarah II Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.10]
11
UNK Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.11]
11
UNk Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.2.12]
10
John of Albermarle-Kentucky Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.3]
b. 1770 d. 1820
11
Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.3.1]
b. 1790
11
Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.3.2]
b. 1792
11
Charles D. Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.3.3]
b. 1795 d. 1865
12
Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.3.3.1]
11
Alexander Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.3.4]
b. 1798 d. 1870
11
John Sylvester of Waynesville Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.3.5]
b. 22 Nov 1800 d. 10 Jan 1857
11
Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.3.6]
b. 1802
11
Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.3.7]
b. 1804
11
Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.3.8]
b. 1805
11
Mary? Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.3.9]
b. 1806
11
Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.3.10]
b. 1808
11
Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.3.11]
b. 1810
10
Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.1.4]
b. 1772
9
John Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.2]
b. 1738
9
Benjamin Strange, Sr.
[1.1.1.1.1.9.10.1.3]
b. 1740
10
John of Knox Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.3.1]
b. 3 Sep 1759 d. 1841
Martha Thurman
11
Benjamin Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.3.1.1]
b. 1798
Mary Polly Johnson
12
John Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.3.1.1.1]
b. 1829 [
=>
]
10
Benjamin Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.9.10.1.3.2]
b. 1762 d. 1820
11
Benjamin Strange, III
[1.1.1.1.1.9.10.1.3.2.1]
b. 1796
11
Dorothy Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.3.2.2]
b. 1798
+
Thurman
10
Mary Hamner Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.3.3]
b. 1765
Joel Appling
11
Jesse WIlliam Appling
[1.1.1.1.1.9.10.1.3.3.1]
b. 1783
+
UNK
10
Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.3.4]
b. 1768
10
Possible Doshea {Thurman} Tyler Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.3.5]
b. 1770
+
Robert Thurman
9
Thomas Strange
[1.1.1.1.1.9.10.1.4]
b. 1744
8
Benjamin Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2]
b. 14 Mar 1715 d. 1779
9
Julius Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.1]
b. 1740
9
William Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.2]
b. 1738 d. 1773
10
Jesse? Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.2.1]
b. 1762
11
Henry Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.2.1.1]
b. 1780 d. Bef Sep 1843
Lindsay Elizabeth Watts
b. 1790 d. Abt 1843
12
Samuel Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.2.1.1.1]
b. 22 Feb 1802 d. 21 Dec 1895
12
Calvin Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.2.1.1.2]
b. 1822 d. 2 Jun 1904
12
James A. Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.2.1.1.3]
b. 2 Jan 1812 d. 24 Jul 1892 [
=>
]
12
Parthena Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.2.1.1.4]
b. 1810
12
Martin Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.2.1.1.5]
12
Irene Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.2.1.1.6]
12
Paul Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.2.1.1.7]
12
Eusebia Nancy Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.2.1.1.8]
12
John C. Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.2.1.1.9]
12
Roland Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.2.1.1.10]
12
Benjamin Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.2.1.1.11]
b. 1830 d. 1919
9
Littleberry Strange
[1.1.1.1.1.9.10.2.3]
b. 1735
8
Francis Strange
[1.1.1.1.1.9.10.3]
b. 11 Nov 1718
8
Elizabeth Strange
[1.1.1.1.1.9.10.4]
b. 7 Feb 1714
8
Janet Strange
[1.1.1.1.1.9.10.5]
b. 10 Dec 1715
7
Thomas Strange
[1.1.1.1.1.9.11]
b. 1687 d. 1742
Mary Owen(s)
8
Owen Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1]
b. 23 Jan 1716
Elizabeth Sisson
9
John Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.1]
b. 1744 d. 1842
10
James Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.1.1]
b. 1790
9
Stephen Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.2]
9
David Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.3]
b. 1748
Susanna Sullivant
10
Henry Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.3.1]
b. 1768
10
David Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.9.11.1.3.2]
b. 1770
11
Peggy Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.3.2.1]
+
Daniel Gould
11
William Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.3.2.2]
+
Nancy Booton
9
William Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.4]
b. 1758 d. 1835
9
Owen Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.9.11.1.5]
b. 1762 d. 1840
+
Charlotte
UNK
10
Henry Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.5.1]
b. 1790
+
Nancy Ferguson
10
William Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.5.2]
b. 1794
+
Nancy Shelton
9
Benjamin Strange, Sr.
[1.1.1.1.1.9.11.1.6]
b. 1765 d. 1846
10
Benjamin Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.1]
b. 1790
Charlotte*
11
Susan Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.1.1]
b. 1816
+
Clark
11
UNNAMED
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.1.2]
10
Henry Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.2]
b. 1792
10
William Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.3]
b. 1794
10
Edward Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.4]
b. 1796
10
Willmoth Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.5]
b. 1794
+
Thomas N. Clarke
+
Nolley
10
John S. Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.6]
b. 1805
11
John Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.6.1]
b. 1828
12
John M. Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.6.1.1]
b. 1855 d. 1930 [
=>
]
11
Hubert Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.6.2]
b. 1831
Sally
12
Florence Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.6.2.1]
b. 1867
12
Vida Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.6.2.2]
b. 1874
12
Hubert Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.6.2.3]
b. 1876
10
Owen Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.6.7]
b. 1810
9
Francis Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.7]
9
Mary Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.8]
Michael Ozbrook
10
Elizabeth Ozbrook
[1.1.1.1.1.9.11.1.8.1]
Samuel Slate
11
Benjamin S. Slate
[1.1.1.1.1.9.11.1.8.1.1]
b. 1793
+
Sarah Grissom
11
Howard Slate
[1.1.1.1.1.9.11.1.8.1.2]
b. 1800
11
Elizabeth Slate
[1.1.1.1.1.9.11.1.8.1.3]
+
Moses Grissom
11
Nancy Slate
[1.1.1.1.1.9.11.1.8.1.4]
b. 1804
+
Milton Grissom
11
Michale Micah Slate
[1.1.1.1.1.9.11.1.8.1.5]
+
Sarah WIllard
11
Jane H. Slate
[1.1.1.1.1.9.11.1.8.1.6]
+
Reason Bell
11
Samuel Slate
[1.1.1.1.1.9.11.1.8.1.7]
+
Sarah Austin
11
John William Slate
[1.1.1.1.1.9.11.1.8.1.8]
+
Nancy Ann Donoho
10
Michael Ozbrook, Jr.
[1.1.1.1.1.9.11.1.8.2]
10
Sterling Starling Ozbrook
[1.1.1.1.1.9.11.1.8.3]
10
Sarah Ozbrook
[1.1.1.1.1.9.11.1.8.4]
+
Jessy Foster
9
Elizabeth Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.9]
b. 1767
+
Russell
+
John Williams
9
Frances Strange
[1.1.1.1.1.9.11.1.10]
+
Williams
8
Mary Strange
[1.1.1.1.1.9.11.2]
b. 28 Jun 1712
8
David Strange
[1.1.1.1.1.9.11.3]
b. 28 Sep 1714 d. 1714
8
Thomas Strange
[1.1.1.1.1.9.11.4]
b. 24 Aug 1719
7
Mary Strange
[1.1.1.1.1.9.12]
b. 1689 d. 1689
6
Thomas Strange
[1.1.1.1.1.10]
b. 1668
5
Eleanor Strange
[1.1.1.1.2]
b. 1604
+
Michael Mitchell
b. 1610
5
Anne Strange
[1.1.1.1.3]
b. 1609
5
Margaret Strange
[1.1.1.1.4]
b. 1612
5
Agnes Strange
[1.1.1.1.5]
b. 15 Nov 1615
5
Prudence Strange
[1.1.1.1.6]
b. 1618
4
Thomas Strange
[1.1.1.2]
b. 1589
4
Ann Strange
[1.1.1.3]
b. 1582
4
Elizabeth Strange
[1.1.1.4]
b. 1588
4
Agnes Strange
[1.1.1.5]
b. 1579
4
Eleanor Strange
[1.1.1.6]
b. 1 Dec 1585
4
William Strange
[1.1.1.7]
4
Margaret Strange
[1.1.1.8]
4
Mary Strange
[1.1.1.9]
3
Richard Strange
[1.1.2]
b. 1556
3
William Strange
[1.1.3]
3
Mary Strange
[1.1.4]
3
Margaret Strange
[1.1.5]
3
John Strange
[1.1.6]
3
Eleanor Strange
[1.1.7]
3
Elizabeth Strange
[1.1.8]
3
Ann Strange
[1.1.9]
3
Thomas Strange
[1.1.10]
b. 18 Mar 1554