Strange DNA
Merging paper sources with DNA to Ancient Roots to Ireland, Scotland & Scandinavia through Europe to Armenia.
First Name
Last Name
[Advanced Search]
[Surnames]
Home
Search
Login
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
What's New
Most Wanted
Reports
Dates
Calendar
Cemeteries
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Recordings
Videos
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Bookmarks
Contact Us
Print
Bookmark
Search
•
Advanced Search
•
Search Families
•
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Agnes
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Agnes
[1]
William Mitchell
b. 1462
2
John Mitchell
[1.1]
b. 1490 d. Aug 1590
Jane Killigrew
3
Thomas Mitchell
[1.1.1]
b. 1520
4
Thomas Michael Mitchell, Sr.
[1.1.1.1]
b. 1550 d. 1620
Agnes
5
John Mitchell
[1.1.1.1.1]
b. 1576
Elizabeth
6
Agnes Mitchell
[1.1.1.1.1.1]
b. 10 Aug 1606
Thomas Morris
7
Phebe Morris
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 30 Aug 1642 d. 1710
John X Strange, I
b. 6 Feb 1621 d. 1686
8
Alexander Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1665 d. 2 Sep 1725
Anne Sammis
9
Henry S. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1695 d. 1745
Mary Liptrop
b. 1695 d. 1750
10
Edmond Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 9 Jan 1729 d. 1800
Mary Spencer
11
Amos Alexander Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1 Nov 1759 d. 1 Jun 1842
Frances Bailey
b. Oct 1774
12
William Bradford Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 8 Dec 1791 d. 22 Mar 1848 [
=>
]
12
Little Berry Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 2 Jul 1807 d. 27 May 1888
12
Mary E. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
12
Marshall Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
12
Rebecah Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
12
Rachel Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6]
12
Permela Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7]
12
Amos Bradford Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 1 Nov 1789 d. 1875 [
=>
]
10
Mitchell Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 11 Aug 1726 d. 1788
Elizabeth Tucker
b. Abt 1725
11
Michael Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 1748
Mary Ellis
12
Susanna Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1]
12
Edmond Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2]
12
*Stephen Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 1766 d. 1830 [
=>
]
11
Littleberry Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 1758
11
Isham Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3]
11
Rachel Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4]
11
Ephriam Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.5]
11
Susanna Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.6]
11
Edmond Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7]
11
Henry Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8]
10
Elizabeth Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
10
James Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
10
Jane Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
10
Henry Strange, II
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6]
10
Gideon Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7]
9
Mitchell Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 22 Oct 1693 d. Abt 1711
9
Judith Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 16 Oct 1696
9
Michael Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 22 Dec 1698
9
Elizabeth Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 5 Apr 1702
9
Anne Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 11 Jun 1704
9
Robert Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 5 Jan 1707
9
Elinor Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 2 Jan 1709
9
Agnes Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.9]
Anne Jenkins
9
Alexander Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.10]
b. 18 Oct 1691
Sarah
10
Joseph Strange, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.1]
b. 14 Mar 1716 d. 1749
11
Joseph of Albermarle Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1]
b. 1736 d. 1782
12
James E. Strange, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.1]
b. 1760 d. 1835 [
=>
]
12
David of Albermarle Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.2]
b. 1764 d. 1841 [
=>
]
12
John of Albermarle-Kentucky Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.3]
b. 1770 d. 1820 [
=>
]
12
Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1.4]
b. 1772
11
John Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.2]
b. 1738
11
Benjamin Strange, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.3]
b. 1740
12
John of Knox Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.3.1]
b. 3 Sep 1759 d. 1841 [
=>
]
12
Benjamin Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.3.2]
b. 1762 d. 1820 [
=>
]
12
Mary Hamner Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.3.3]
b. 1765 [
=>
]
12
Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.3.4]
b. 1768
12
Possible Doshea {Thurman} Tyler Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.3.5]
b. 1770
11
Thomas Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.4]
b. 1744
10
Benjamin Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.2]
b. 14 Mar 1715 d. 1779
11
Julius Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.1]
b. 1740
11
William Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.2]
b. 1738 d. 1773
12
Jesse? Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.2.1]
b. 1762 [
=>
]
11
Littleberry Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.3]
b. 1735
10
Francis Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.3]
b. 11 Nov 1718
10
Elizabeth Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.4]
b. 7 Feb 1714
10
Janet Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.10.5]
b. 10 Dec 1715
9
Thomas Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11]
b. 1687 d. 1742
Mary Owen(s)
10
Owen Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1]
b. 23 Jan 1716
Elizabeth Sisson
11
John Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1]
b. 1744 d. 1842
12
James Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1]
b. 1790
11
Stephen Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.2]
11
David Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.3]
b. 1748
Susanna Sullivant
12
Henry Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.3.1]
b. 1768
12
David Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.3.2]
b. 1770 [
=>
]
11
William Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.4]
b. 1758 d. 1835
11
Owen Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.5]
b. 1762 d. 1840
+
Charlotte
UNK
12
Henry Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.5.1]
b. 1790
12
William Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.5.2]
b. 1794
11
Benjamin Strange, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.6]
b. 1765 d. 1846
12
Benjamin Strange, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.6.1]
b. 1790 [
=>
]
12
Henry Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.6.2]
b. 1792
12
William Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.6.3]
b. 1794
12
Edward Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.6.4]
b. 1796
12
Willmoth Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.6.5]
b. 1794
12
John S. Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.6.6]
b. 1805 [
=>
]
12
Owen Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.6.7]
b. 1810
11
Francis Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.7]
11
Mary Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.8]
Michael Ozbrook
12
Elizabeth Ozbrook
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.8.1]
[
=>
]
12
Michael Ozbrook, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.8.2]
12
Sterling Starling Ozbrook
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.8.3]
12
Sarah Ozbrook
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.8.4]
11
Elizabeth Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.9]
b. 1767
+
Russell
+
John Williams
11
Frances Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.10]
+
Williams
10
Mary Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.2]
b. 28 Jun 1712
10
David Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.3]
b. 28 Sep 1714 d. 1714
10
Thomas Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.11.4]
b. 24 Aug 1719
9
Mary Strange
[1.1.1.1.1.1.1.1.12]
b. 1689 d. 1689
8
Thomas Strange
[1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1668
+
John Chandler
d. Abt Feb 1698
7
Agnes Morris
[1.1.1.1.1.1.2]
b. Sep 1637
7
Thomas Morris
[1.1.1.1.1.1.3]
b. 26 Dec 1644
6
Alice Mitchell
[1.1.1.1.1.2]
b. 1602
6
John Mitchell
[1.1.1.1.1.3]
b. 19 Dec 1609
6
Elizabeth Mitchell
[1.1.1.1.1.4]
b. 10 Oct 1595
5
Thomas Michael Mitchell, Jr.
[1.1.1.1.2]
b. 1572 d. 1642
Elizabeth
6
Thomas Mitchell Michell, I
[1.1.1.1.2.1]
b. 1 Nov 1612 d. May 1690
Mary
7
Thomas Mitchell, II
[1.1.1.1.2.1.1]
b. 30 Apr 1659 d. 6 Jan 1736
Mary Gregory
8
Thomas Mitchell, III
[1.1.1.1.2.1.1.1]
b. 3 Jan 1701 d. 3 Oct 1776
Elizabeth Bynum
b. Abt 1702
9
Archelaus Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1]
b. 27 Jul 1725 d. 1792
Mary Gregory
10
William Mitchell, I
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 1768 d. 1838
Elizabeth
11
William Thomas Mitchell, II
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1]
b. 1802 d. 1841
Rachael Garrett
b. 1805 d. 22 Nov 1880
12
Thomas Humphey Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1]
b. 9 Jan 1823 d. 29 Sep 1887 [
=>
]
12
Christopher Thomas Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1833 d. 22 Jul 1864
12
William Phillip Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.3]
b. 1825 d. 1865
12
Martha Jane Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1832 d. Bef 1900 [
=>
]
12
Robert Garrett Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.5]
b. 1837 d. 8 May 1864 [
=>
]
12
? John G. Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.6]
12
? Abner Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.7]
10
Abner Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.2]
b. 1760 d. 1832
10
David Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.3]
b. 1762
10
Anne Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4]
b. 9 Mar 1766 d. 1825
Archelaus Mitchell Major Perkins
b. 1760 d. 1849
11
Mary Gregory Perkins
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1]
b. 12 Jul 1786 d. 29 Sep 1845
William Clayburn Alloway Strange, of Rock Rest
b. 23 Jul 1783 d. 30 Aug 1841
12
Archer Perkins Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1]
b. 12 Mar 1808
12
John B. Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.2]
b. 16 Aug 1809 d. 26 Apr 1888
12
Mildred Ann Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.3]
b. 1 Aug 1811 d. 1887
12
Mary Reed Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.4]
b. 13 Jun 1813 d. 1882 [
=>
]
12
Gideon Elijah M. Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.5]
b. Jun 1815 d. 6 May 1909 [
=>
]
12
Sarah E. Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.6]
b. 25 Jun 1817
12
Lucy M. Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.7]
b. 25 Nov 1819
12
William George Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.8]
b. 22 Apr 1823 d. 21 Nov 1887 [
=>
]
12
Eurebia Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.9]
b. 15 Sep 1825
11
Lucy M. Perkins
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.2]
d. 14 Sep 1835
11
Ann R. Perkins
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.3]
b. 1793 d. 1872
James Herndon
b. 1791 d. 1857
12
Isaac O. Herdon
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.3.1]
[
=>
]
12
John G. Herndon
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.3.2]
b. 1815 d. 1905 [
=>
]
12
Martha Herndon
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.4.3.3]
b. 1831 [
=>
]
10
Gideon Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.5]
b. 1772
10
Archelaus Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.6]
b. 23 Jan 1776
11
Bowling Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.6.1]
11
Thomas Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.6.2]
11
Archelaus Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.6.3]
b. 1794
9
Anne [Mildred] Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.2]
b. 3 Jan 1728 d. 1781
John Alloway of Fluvanna, Oak Hill Strange, IV
b. 15 Jan 1727 d. 1 Sep 1811
10
Abner Alloway Strange, of Elk River
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1]
b. 14 Mar 1761 d. 27 Aug 1835
Elizabeth Mitchell
b. 14 Oct 1756 d. 22 Jan 1803
11
Nancy Ann Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1]
b. 1797
+
Charles Mitchell Bernard
b. 11 Feb 1788
11
Martha M. Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.2]
b. 4 Sep 1799
+
Flanagan
11
Edward Saunders ? Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.3]
b. Abt 1785
11
Judith Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.4]
d. Bef 1834
11
Mildred A. Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.5]
d. Bef 1834
11
Thomas M. A. Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.6]
d. 18 Dec 1855
11
John Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.7]
11
Eleanore Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.8]
b. 8 Feb 1782
11
Gideon M. Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.9]
b. 1783
11
Abner Alloway Strange, Jr.
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.10]
b. 1788
11
Rebecca Ann Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.11]
b. 1800
10
Abraham Alloway Strange, of Upper Yadkin
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2]
b. 1746 d. 1815
Mary Molly Moore
b. 1758 d. 10 Nov 1842
11
Nancy Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1]
b. 1779 d. Aft 1843
Solomon Israel
b. 1774
12
UNK Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1]
12
Rebecca Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1.2]
12
Michael Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1.3]
b. 1802
12
Abraham Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1.4]
b. 1808
12
Isom Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1.5]
b. 1812
12
Pleasant Walker Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1.6]
b. 16 Mar 1816 d. 28 Feb 1901
12
George Nelson Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1.7]
b. 8 Dec 1819 d. 1890 [
=>
]
12
Felix Walker Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1.8]
b. 1820
11
Archelaus Alloway Strange, of Crocus Creek
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2]
b. 12 Jul 1780 d. 23 Oct 1852
Elizabeth Coffey
b. 10 Jan 1782 d. 16 Sep 1853
12
John Claiborne Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2.1]
b. 4 Nov 1804 d. 1865 [
=>
]
12
William Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2.2]
b. 11 Dec 1805 d. 20 Mar 1845 [
=>
]
12
Abraham A. Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2.3]
b. 3 Mar 1808 d. 10 Aug 1866 [
=>
]
12
Lewis Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2.4]
b. 19 Mar 1810 d. 10 Jan 1886 [
=>
]
12
Archelaus Alloway Strange, Jr.
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2.5]
b. 13 Sep 1812 d. 26 May 1884 [
=>
]
12
Allen Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2.6]
b. 18 Dec 1813 [
=>
]
12
Mary Viamby Polly Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2.7]
b. 31 Dec 1814
12
William Levi A. ??? Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2.8]
b. 1 Apr 1817 d. 3 Dec 1882 [
=>
]
12
Larkin Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2.9]
b. 9 May 1819 d. 25 Aug 1884 [
=>
]
12
Winston Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2.10]
b. 13 Mar 1821 d. Jan 1900 [
=>
]
12
Elizabeth Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2.11]
b. Apr 1823 [
=>
]
12
Ellen Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2.12]
b. 1825
11
John Walker S. Alloway of Jennings & Jasper Dropped Strange - Used ALLOWAY, Sr.
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3]
b. 27 Sep 1781 d. 2 May 1863
Elizabeth Waters
12
Nancy Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.1]
b. 19 Jan 1806
12
Sarah Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.2]
b. 1808
Jane Curtis
12
john Thomas Alloway Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.3]
b. 1813 [
=>
]
12
Alfred Alloway Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.4]
b. 1817 [
=>
]
12
Allen Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.5]
b. 1817 [
=>
]
12
Susannah Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.6]
b. 1820 [
=>
]
12
Caroline Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.7]
b. 1822
12
Abijah Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.8]
b. 16 Jun 1824 d. 3 Dec 1874 [
=>
]
12
Abisha Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.9]
b. 16 Jun 1824 d. 10 Nov 1863 [
=>
]
12
Nelson Dropped Strange - Used ALLOWAY, Sr.
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.10]
b. Abt 1826 d. Aft 1885 [
=>
]
Anna Mary Barns
b. Abt 1791
12
Amanda Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.11]
12
Alabama Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.12]
12
ELizabeth Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.13]
11
Wilson Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.4]
b. 1784 d. Bef 28 Jun 1843
11
Judy Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.5]
b. 1786 d. Abt 1819
+
Isom Israel
11
Elizabeth Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.6]
b. 25 May 1787 d. 29 Jul 1856
+
Johnson
11
Susannah Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.7]
b. 1788 d. Bef 1843
+
Coffey
11
Hannah S. Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.8]
b. 13 Feb 1790 d. 14 Feb 1871
+
Coffey
11
Abraham T. Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.9]
b. 1792 d. Sep 1870
11
William Alloway *no kids Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.10]
b. 1794 d. 1843
11
Polly Alloway *no kids Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.11]
b. 1796 d. Bef 1847
11
Nelson Alloway Strange, Sr.
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.12]
b. 1799 d. 29 Jul 1842
11
WIlson Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.13]
b. 1784
Sally
12
Hannah Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.13.1]
12
Elizabeth Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.13.2]
12
John Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.13.3]
12
Albert Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.13.4]
12
Nelson Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.13.5]
12
Mary Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.13.6]
12
WIlliam A. Strange, Jr.
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.13.7]
12
Nancy Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.13.8]
11
Judy Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.14]
b. 1785
Isom Israel
12
Polly Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.14.1]
b. 1801 d. 1804
12
Mahala Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.14.2]
b. 1802
12
Archibald Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.14.3]
b. 1805
12
Michael Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.14.4]
b. 1810
12
Jesse Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.14.5]
b. 1815
12
UNK Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.14.6]
b. 1817
12
Nelson Israel
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.14.7]
b. 1819
11
Elizabeth Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.15]
b. 25 May 1787 d. 29 Jul 1856
+
John Johnson
11
Susannah Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.16]
b. 1788
+
William COFFEY
11
Hannah Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.17]
b. 18 Feb 1790
James Coffey
12
Archelaus Coffey
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.17.1]
12
Sally Coffey
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.17.2]
12
Abraham Coffey
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.17.3]
12
Mary Coffey
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.17.4]
12
Riley Coffey
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.17.5]
12
John Davidson Coffey
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.17.6]
12
Elvira Ann Coffey
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.17.7]
11
Abraham T. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.18]
b. 1792 d. 1870
Mary Loving
12
Lora Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.18.1]
12
John F. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.18.2]
b. Abt 1813 [
=>
]
12
Mary D. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.18.3]
12
Nelson Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.18.4]
12
Azor Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.18.5]
12
James T. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.18.6]
12
Angeline T. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.18.7]
12
Abraham T. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.18.8]
b. 1832
11
William Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.19]
b. 1796
11
Polley Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.20]
b. 1797
11
Nelson Alloway Strange, Sr.
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.21]
b. 25 Feb 1799
+
Susan Corpening
+
Ann Corpening
10
Archelaus S. “Archer” Alloway Strange, of Boone
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.3]
b. 1748 d. 20 Aug 1808
Elizabeth Vannerson
b. 1753
11
John S. Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.3.1]
b. 22 Sep 1782 d. 2 May 1863
10
Mary “Molly” Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.4]
b. 1752 d. 1811
+
Bell
10
Rebecca Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.5]
b. 1754 d. 14 Apr 1841
+
Sanders
10
John Alloway “Jesse” Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.6]
b. 1755 d. 1800
10
Martha Patsey Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.7]
b. 22 Sep 1756 d. 13 Sep 1831
10
Francis A. “Grandby” Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.8]
b. 1764 d. 19 Feb 1851
Benjamin Bowles
11
Rebecca Mitchell Bowles
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.8.1]
11
Jesse T. Bowles
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.8.2]
12
Malvina Virginia Bowles
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.8.2.1]
9
Thomas Bartlett Mitchell, IV
[1.1.1.1.2.1.1.1.3]
b. 16 Jul 1730 d. 1767
Judith Moss
10
Elizabeth Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.1]
b. 14 Oct 1756 d. 22 Jan 1803
Abner Alloway Strange, of Elk River
b. 14 Mar 1761 d. 27 Aug 1835
11
Nancy Ann Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.1]
b. 1797
+
Charles Mitchell Bernard
b. 11 Feb 1788
11
Martha M. Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.2]
b. 4 Sep 1799
+
Flanagan
11
Edward Saunders ? Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.3]
b. Abt 1785
11
Judith Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.4]
d. Bef 1834
11
Mildred A. Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.5]
d. Bef 1834
11
Thomas M. A. Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.6]
d. 18 Dec 1855
11
John Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.7]
11
Eleanore Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.8]
b. 8 Feb 1782
11
Gideon M. Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.9]
b. 1783
11
Abner Alloway Strange, Jr.
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.10]
b. 1788
11
Rebecca Ann Strange
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.1.11]
b. 1800
10
Flood Randolph Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.2]
10
Joab Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.3]
b. 30 Nov 1761
10
Charles Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.4]
b. 13 Mar 1759
Mary Polly Barnett
11
Sarah Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.4.1]
b. 1788
10
Ann Nancy B. Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.5]
b. 28 Oct 1764
Allen Bernard
11
Charles Mitchell Bernard
[1.1.1.1.2.1.1.1.3.5.1]
b. 11 Feb 1788
+
Nancy Ann Strange
b. 1797
9
Rebecca Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.4]
b. 16 Feb 1736
+
Henry Thompson
9
Elizabeth B. Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.5]
b. 1738 d. 25 Mar 1739
SLAVE
9
Nanny Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.6]
b. 25 Sep 1727
9
Cesar Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.7]
b. 15 Oct 1729
9
Dick Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.1.8]
d. 1734
8
Archelaus Bartlett Barnett Mitchell, I
[1.1.1.1.2.1.1.2]
b. 9 Feb 1703
Anne Reed
9
Archelaus Mitchell, Jr.
[1.1.1.1.2.1.1.2.1]
b. 1725 d. 1799
Hannah some say Gregory MN Kirby
10
Archelaus “Gustavus?” Mitchell, III
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1]
b. 1 Jan 1756 d. 1825
Milly Burks
11
Samuel D. Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1]
b. 1784
11
Archelaus Patterson Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.2]
b. 1790
11
?Pleasant? Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.3]
12
Julia Ann Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.3.1]
Spicey Goodwin
11
Jordan D. Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.4]
b. 1794
12
John D. Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.4.1]
b. 1823
12
John William Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.4.2]
12
Robert Alexander Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.4.3]
b. Abt 1820 [
=>
]
12
Robert D. Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.4.4]
11
Micajah G. Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.5]
11
Mourning Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.6]
b. Abt 1792
+
Walter Williams
11
Matilde Mahala Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.7]
9
Susanna Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.2]
b. 1728
+
John Rain
9
William Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.3]
b. 19 Apr 1730 d. 1796
Agnes Payne
10
Anne Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.3.1]
10
Isabella Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.3.2]
9
Lucy Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.4]
b. 18 Jul 1736 d. Aft Jan 1805
+
John Perkins
9
Mary Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.5]
+
Bryce
b. 19 Sep 1738
SLAVE
9
SLAVE Sam Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.2.6]
b. 27 Feb 1734
8
Martha Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.3]
b. 22 Sep 1697
8
Rebecca Mitchell
[1.1.1.1.2.1.1.4]
b. 1699
7
Stephen Mitchell, Sr.
[1.1.1.1.2.1.2]
b. 1644 d. 6 May 1715
Mary
8
Stephen Mitchell, Jr.
[1.1.1.1.2.1.2.1]
b. 1678 d. 18 Apr 1720
Ann
9
John Mitchell
[1.1.1.1.2.1.2.1.1]
b. 19 Dec 1698
9
Stephen Mitchell, III
[1.1.1.1.2.1.2.1.2]
b. 24 Dec 1699
9
Evan Valentine Mitchell
[1.1.1.1.2.1.2.1.3]
b. 16 Jan 1711 d. 27 Jul 1713
9
Mary Mitchell
[1.1.1.1.2.1.2.1.4]
b. 22 Aug 1708
9
Elizabeth Mitchell
[1.1.1.1.2.1.2.1.5]
b. 12 Oct 1704
+
Thomas Scruggs
9
Anne Mitchell
[1.1.1.1.2.1.2.1.6]
b. 20 Jan 1705
9
Valentine? Mitchell
[1.1.1.1.2.1.2.1.7]
b. 27 Sep 1713
9
Leason Mitchell
[1.1.1.1.2.1.2.1.8]
b. 30 May 1724 d. Dec 1726
9
Michael Mitchell
[1.1.1.1.2.1.2.1.9]
8
Hannah Mitchell
[1.1.1.1.2.1.2.2]
b. 1680
+
Matthew Simes
SLAVE
8
SLAVE Stephen Mitchell
[1.1.1.1.2.1.2.3]
b. 17 Aug 1710
7
Elizabeth Mitchell
[1.1.1.1.2.1.3]
b. 1632 d. 1662
John X Strange, I
b. 6 Feb 1621 d. 1686
8
John Strange, II
[1.1.1.1.2.1.3.1]
b. 1662 d. 1730
Elizabeth
9
John “Alloway’s” Strange, III
[1.1.1.1.2.1.3.1.1]
b. 1700 d. 1742
Ann or Galloway Alloway
10
John Alloway of Fluvanna, Oak Hill Strange, IV
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1]
b. 15 Jan 1727 d. 1 Sep 1811
Anne [Mildred] Mitchell
b. 3 Jan 1728 d. 1781
11
Abner Alloway Strange, of Elk River
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.1]
b. 14 Mar 1761 d. 27 Aug 1835
Elizabeth Mitchell
b. 14 Oct 1756 d. 22 Jan 1803
12
Nancy Ann Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.1]
b. 1797
12
Martha M. Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.2]
b. 4 Sep 1799
12
Edward Saunders ? Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.3]
b. Abt 1785
12
Judith Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.4]
d. Bef 1834
12
Mildred A. Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.5]
d. Bef 1834
12
Thomas M. A. Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.6]
d. 18 Dec 1855
12
John Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.7]
12
Eleanore Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.8]
b. 8 Feb 1782
12
Gideon M. Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.9]
b. 1783
12
Abner Alloway Strange, Jr.
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.10]
b. 1788
12
Rebecca Ann Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.1.11]
b. 1800
11
Abraham Alloway Strange, of Upper Yadkin
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2]
b. 1746 d. 1815
Mary Molly Moore
b. 1758 d. 10 Nov 1842
12
Nancy Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.1]
b. 1779 d. Aft 1843 [
=>
]
12
Archelaus Alloway Strange, of Crocus Creek
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.2]
b. 12 Jul 1780 d. 23 Oct 1852 [
=>
]
12
John Walker S. Alloway of Jennings & Jasper Dropped Strange - Used ALLOWAY, Sr.
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.3]
b. 27 Sep 1781 d. 2 May 1863 [
=>
]
12
Wilson Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.4]
b. 1784 d. Bef 28 Jun 1843
12
Judy Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.5]
b. 1786 d. Abt 1819
12
Elizabeth Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.6]
b. 25 May 1787 d. 29 Jul 1856
12
Susannah Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.7]
b. 1788 d. Bef 1843
12
Hannah S. Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.8]
b. 13 Feb 1790 d. 14 Feb 1871
12
Abraham T. Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.9]
b. 1792 d. Sep 1870
12
William Alloway *no kids Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.10]
b. 1794 d. 1843
12
Polly Alloway *no kids Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.11]
b. 1796 d. Bef 1847
12
Nelson Alloway Strange, Sr.
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.12]
b. 1799 d. 29 Jul 1842
12
WIlson Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.13]
b. 1784 [
=>
]
12
Judy Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.14]
b. 1785 [
=>
]
12
Elizabeth Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.15]
b. 25 May 1787 d. 29 Jul 1856
12
Susannah Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.16]
b. 1788
12
Hannah Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.17]
b. 18 Feb 1790 [
=>
]
12
Abraham T. Dropped Strange - Used ALLOWAY
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.18]
b. 1792 d. 1870 [
=>
]
12
William Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.19]
b. 1796
12
Polley Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.20]
b. 1797
12
Nelson Alloway Strange, Sr.
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.2.21]
b. 25 Feb 1799
11
Archelaus S. “Archer” Alloway Strange, of Boone
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.3]
b. 1748 d. 20 Aug 1808
Elizabeth Vannerson
b. 1753
12
John S. Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.3.1]
b. 22 Sep 1782 d. 2 May 1863
11
Mary “Molly” Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.4]
b. 1752 d. 1811
+
Bell
11
Rebecca Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.5]
b. 1754 d. 14 Apr 1841
+
Sanders
11
John Alloway “Jesse” Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.6]
b. 1755 d. 1800
11
Martha Patsey Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.7]
b. 22 Sep 1756 d. 13 Sep 1831
11
Francis A. “Grandby” Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.8]
b. 1764 d. 19 Feb 1851
Benjamin Bowles
12
Rebecca Mitchell Bowles
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.8.1]
12
Jesse T. Bowles
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.8.2]
[
=>
]
Mildred Ann “Milly” Barnett
11
William Clayburn Alloway Strange, of Rock Rest
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.9]
b. 23 Jul 1783 d. 30 Aug 1841
Mary Gregory Perkins
b. 12 Jul 1786 d. 29 Sep 1845
12
Archer Perkins Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.9.1]
b. 12 Mar 1808
12
John B. Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.9.2]
b. 16 Aug 1809 d. 26 Apr 1888
12
Mildred Ann Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.9.3]
b. 1 Aug 1811 d. 1887
12
Mary Reed Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.9.4]
b. 13 Jun 1813 d. 1882 [
=>
]
12
Gideon Elijah M. Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.9.5]
b. Jun 1815 d. 6 May 1909 [
=>
]
12
Sarah E. Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.9.6]
b. 25 Jun 1817
12
Lucy M. Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.9.7]
b. 25 Nov 1819
12
William George Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.9.8]
b. 22 Apr 1823 d. 21 Nov 1887 [
=>
]
12
Eurebia Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.9.9]
b. 15 Sep 1825
11
George Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.10]
b. 1786 d. 1837
11
Sarah Maria “Sally” Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.11]
b. 5 Apr 1788 d. 4 Aug 1852
11
Col. Gideon Alloway Strange, I - of Dog Point
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12]
b. 7 Mar 1793 d. 23 Feb 1838
Harriet Magruder
d. 1829
12
Edward Magruder Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.1]
b. 1817 [
=>
]
12
James Magruder Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.2]
b. 8 Aug 1818 [
=>
]
12
Sarah W. Willie Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.3]
b. 1819 d. Mar 1844
12
Ann Mildred Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.4]
b. 1821 [
=>
]
12
Harriet V. Hattie Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.5]
b. Feb 1822 d. 13 Aug 1859 [
=>
]
12
Col. John Bouie Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.6]
b. 1823 d. 1862 [
=>
]
12
Gideon Alloway Strange, II
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.7]
b. 1825 d. 1899 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.8]
b. 15 Jan 1829 d. 12 Nov 1898
Mary B. Gay
b. 1794 d. 1879
12
Charles Windham Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.9]
12
Henry Erskin Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.10]
12
Frances B. Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.11]
12
Lizzie E. Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.12]
12
William Gay Alloway Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.13]
b. 1833 d. 1877
12
Agatha Estell Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.14]
12
Caroline Scott Strange
[1.1.1.1.2.1.3.1.1.1.12.15]
8
Mitchell Strange
[1.1.1.1.2.1.3.2]
b. 1660 d. 20 Apr 1717
+
Elizabeth
8
Benjamin Strange
[1.1.1.1.2.1.3.3]
b. 1650 d. 1675
8
Henry Strange
[1.1.1.1.2.1.3.4]
b. 1652 d. 1710
8
Elizabeth Strange
[1.1.1.1.2.1.3.5]
b. 1654
8
Anne Strange
[1.1.1.1.2.1.3.6]
b. 1656
+
Robert Hughes
8
Margaret Strange
[1.1.1.1.2.1.3.7]
b. 1659
8
Amos Strange
[1.1.1.1.2.1.3.8]
7
Agnes Mitchell
[1.1.1.1.2.1.4]
b. 1634 d. 1679
7
Anne Mitchell
[1.1.1.1.2.1.5]
b. 1635
+
William Bartlet
7
Michael Mitchell
[1.1.1.1.2.1.6]
b. 1638
7
Mary Mitchell
[1.1.1.1.2.1.7]
b. 1640
+
Matthew Rowley
7
Hannah Mitchell
[1.1.1.1.2.1.8]
b. 1648
7
Alexander Mitchell
[1.1.1.1.2.1.9]
b. 1652
+
Anne Alloway
7
Martha Mitchell
[1.1.1.1.2.1.10]
b. 1655
6
Judith Mitchell
[1.1.1.1.2.2]
b. 28 Jul 1603 d. 6 Aug 1603
6
Michael Mitchell
[1.1.1.1.2.3]
b. 1610
+
Eleanor Strange
b. 1604
6
Mary Mitchell
[1.1.1.1.2.4]
b. 1608
6
Joan Mitchell
[1.1.1.1.2.5]
b. 1605
+
William Roe
6
Agnes Mitchell
[1.1.1.1.2.6]
b. 28 Jul 1603 d. 5 Aug 1603
6
Anne Mitchell
[1.1.1.1.2.7]
b. 1612
William Tucker
7
Michael Tucker
[1.1.1.1.2.7.1]
b. Abt 1637
8
UNK Tucker
[1.1.1.1.2.7.1.1]
b. Abt 1660
9
UNK Tucker
[1.1.1.1.2.7.1.1.1]
b. Abt 1680
10
Isham Tucker
[1.1.1.1.2.7.1.1.1.1]
b. Abt 1700
11
Elizabeth Tucker
[1.1.1.1.2.7.1.1.1.1.1]
b. Abt 1725
Mitchell Strange
b. 11 Aug 1726 d. 1788
12
Michael Strange
[1.1.1.1.2.7.1.1.1.1.1.1]
b. 1748 [
=>
]
12
Littleberry Strange
[1.1.1.1.2.7.1.1.1.1.1.2]
b. 1758
12
Isham Strange
[1.1.1.1.2.7.1.1.1.1.1.3]
12
Rachel Strange
[1.1.1.1.2.7.1.1.1.1.1.4]
12
Ephriam Strange
[1.1.1.1.2.7.1.1.1.1.1.5]
12
Susanna Strange
[1.1.1.1.2.7.1.1.1.1.1.6]
12
Edmond Strange
[1.1.1.1.2.7.1.1.1.1.1.7]
12
Henry Strange
[1.1.1.1.2.7.1.1.1.1.1.8]
6
Elizabeth Mitchell
[1.1.1.1.2.8]
b. 1615
+
John Jennings
5
Agnes Mitchell
[1.1.1.1.3]
b. 3 Sep 1575
5
Stephen Mitchell
[1.1.1.1.4]
b. 1578
3
John Mitchell
[1.1.2]
b. 1515
Agnes Vye
4
John Mitchell
[1.1.2.1]
b. 26 Sep 1544 d. 2 Jun 1620
+
Emily Weeks
4
Thomas Mitchell
[1.1.2.2]
b. 19 Aug 1550
+
Honure Robyns Tyler
4
Alexander Mitchell
[1.1.2.3]
b. 1552