Strange DNA
Merging paper sources with DNA to Ancient Roots to Ireland, Scotland & Scandinavia through Europe to Armenia.
First Name
Last Name
[Advanced Search]
[Surnames]
Home
Search
Login
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
What's New
Most Wanted
Reports
Dates
Calendar
Cemeteries
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Recordings
Videos
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Bookmarks
Contact Us
Print
Bookmark
Search
•
Advanced Search
•
Search Families
•
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Elizabeth Colman
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Elizabeth Colman
[1]
Edward of Saxham County Newton Alston
2
William of Saxham Hall Alston
[1.1]
b. 1537 d. 13 Jan 1617
Elizabeth Daughter & Co-Heir of Hapstead Bindloss
3
Thomas of Gedding Hall Alston
[1.1.1]
d. 25 Jan 1619
Frances Bloomfield
d. 1678
4
John of the Inner Temple Alston, I
[1.1.1.1]
b. 1610 d. 16 Aug 1687
Dorothy Temple
5
John Alston, II
[1.1.1.1.1]
d. 1704
Anne Wallis
6
John Alston, III
[1.1.1.1.1.1]
b. 5 Dec 1673 d. 17 Sep 1755
Mary Clarke
b. 1674
7
Colonel Solomon Alston, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 1701 d. 18 Apr 1784
Nancy Ann Hinton
b. 1714
8
[Christian] Charity [Elizabeth] Alston
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 19 Jan 1743 d. Mar 1774
Captain James David Jones
b. 1730 d. 10 Sep 1777
9
James Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1765 d. 15 Aug 1843
Charity Elizabeth by death cert.???????????
b. 1775 d. Apr 1860
10
Isaac Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 29 Dec 1801 d. 22 Jan 1876
Alcinda Trail?
b. 1817 d. Aft 1880
11
Edward W. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1843
Martha
b. 1843
12
Andrew 1868
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1868 d. 10 Jul 1881
12
Lucy Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1871
12
Louis C. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 1873
12
Charles Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1876
12
Erba Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 1880
11
Julia A. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1844
+
W. T. Aden
11
Lucinda Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. May 1845
11
Louis C. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1848
11
Electra “Letty” Sara Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 4 Feb 1852 d. 23 Feb 1934
John Milton Merritt
b. 7 Jan 1853 d. 9 Dec 1950
12
William Chatham Merritt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.1]
b. 6 Dec 1873 d. 2 Feb 1939
12
Thomas Merritt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.2]
b. 1875
12
John Finn Merritt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.3]
b. 21 Jul 1875 d. 27 Mar 1841
12
Lou Annie Merritt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.4]
12
Louis Turpin Merritt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5]
12
Belle Merritt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.6]
11
Erastis Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 1854
Moore?
11
Archibald A. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 27 Nov 1827 d. 19 Feb 1906
Lucetta J Woods
b. 6 Aug 1827 d. 8 Feb 1864
12
Emelia Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1]
b. 1851 d. 24 Sep 1927
12
Franklin Pierce Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2]
b. 20 Nov 1852 d. 5 May 1912
12
Mary F. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3]
b. 1853 d. 20 Oct 1940
12
James Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4]
b. Sep 1854 d. 1920
12
Samuel Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5]
b. Jul 1857
12
Hellen Ann Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6]
b. 10 Nov 1858 d. 8 Nov 1953 [
=>
]
12
Goergia Ann Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.7]
b. 1859
12
Delia C. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.8]
b. 1863
12
Martha J. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.9]
b. 1864
+
Emilie
11
Isaac Carroll Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 28 Jan 1833 d. 4 Sep 1917
Sidney Ann Smith
b. 8 May 1834 d. 4 Aug 1890
12
Anderson Pope Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1]
b. 9 Mar 1857 d. 27 Jun 1937 [
=>
]
12
James E. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.2]
b. 10 Oct 1858 d. 24 Aug 1935 [
=>
]
12
Isaac Paton Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.3]
b. 24 Sep 1860
12
John Aaron Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.4]
b. 2 Dec 1862
12
Uriah Elgin “El” Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.5]
b. 9 Oct 1867 d. 22 Aug 1936 [
=>
]
12
Alexander L. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.6]
b. 24 Mar 1865 [
=>
]
12
Robert Hill Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.7]
b. 17 May 1870 [
=>
]
12
Lona Belle Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.8]
b. 4 Aug 1873 d. 29 Apr 1947 [
=>
]
11
Lucetta “Letty” Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 1829
11
Uriah Elgin Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10]
b. 1830 d. 1870
Julia A. Smith
b. 1835 d. 1870
12
Arthur Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1]
12
Mary Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.2]
12
Emily Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.3]
b. 1863
12
Lacinda Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4]
b. 1865
12
Martha J. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.5]
b. 1868
11
Mary Elizabeth Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11]
b. 1836
+
Ransom Smith
11
Susan Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12]
b. 1837 d. 5 Oct 1900
+
J. A. Marler
10
Enoch Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 17 Sep 1790 d. 3 Feb 1878
10
Sarah “Sally” Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 1794 d. 1870
10
Eurica Arick “Erick” Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1796 d. 5 Mar 1866
Martha Pigg
b. 1800 d. 1860
11
William C. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 1818 d. 1870
11
Elizabeth Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 1830
11
Jackson Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3]
b. 1831
11
Emeline Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 1832 d. 1866
11
Martha Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.5]
b. 1836
11
Hezekiah Lee Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.6]
b. 1838 d. 24 Mar 1878
11
Issac Carroll Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.7]
b. 14 Feb 1841 d. 9 Feb 1903
10
Eurica Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 1796 d. 5 Mar 1866
10
Bethina Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 1798 d. 1860
10
Matthew J. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 1805
10
Alsa Alsey Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 1808 d. 14 Oct 1878
Melvinna Lavina “Vina” Moore
b. 1805 d. 13 Jul 1889
11
Mathew Jenkins Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1]
b. 17 Jan 1835 d. 25 Feb 1923
Nancy Jane Mullican
b. 26 Jan 1838 d. Oct 1895
12
Andrew Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1.1]
b. 11 Nov 1857 d. 22 May 1913
12
Horace Francis Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1.2]
b. 8 Oct 1859 d. 17 Feb 1896 [
=>
]
12
Harris Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1.3]
b. 1860
12
Mattie McBrear Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1.4]
b. 2 Aug 1862 d. 29 Dec 1950
12
Sarah F. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1.5]
b. Sep 1862
12
Anna Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1.6]
b. 1 Jan 1865
12
Theodocia Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1.7]
b. 13 Nov 1865 d. 22 Dec 1905
12
Susannah Paralee Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1.8]
b. 12 Jul 1868 d. 31 Jan 1961
12
Jesse London Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1.9]
b. 26 Sep 1870 d. 28 Mar 1918
12
Callie Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1.10]
b. 1874 d. 9 Nov 1878
12
Thomas Richard Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1.11]
b. 13 Jun 1877 d. 15 Oct 1956
11
Jacob Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.2]
b. 1840
11
Susan E. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.3]
b. 1 Nov 1843 d. Mar 1910
11
James R Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.4]
b. 6 Jan 1844 d. 11 Feb 1897
11
!Eliza Jane! Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.5]
b. 1 Oct 1829 d. 2 May 1908
11
!Martha Jane! Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.6]
b. 1832
11
Marcus Calhoun Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.7]
b. 16 Dec 1849 d. 2 Feb 1932
11
Violet Cinderella Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.8]
b. 1850 d. 1941
11
!Catherine! Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.9]
10
Mark Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 1807
10
John C. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10]
b. 1811 d. 1870
10
Zachariah Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.11]
b. 9 Apr 1812 d. 1879
10
William B. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.12]
b. 1816 d. Mar 1880
9
Mary Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1760
9
Prascilla “Prissey” Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 1762
9
Willis Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1766 d. 11 Jul 1851
9
Rachel Alston Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 6 May 1769 d. 14 Jul 1851
Ralph Banks
10
James Jones Banks
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.1]
Hannah Alston
11
Jabez Benoni Banks
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.1.1]
Jane Rebecca Harvey
12
James Jones Banks
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.1.1.1]
b. 27 Apr 1861 d. 13 Dec 1946 [
=>
]
11
Newton Paley Banks
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.1.2]
Frances J erringam?
12
Pearl Banks
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.1.2.1]
[
=>
]
10
Ralph Banks, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.2]
b. 6 Apr 1796 d. 21 Apr 1871
Elizabeth Maxwell
11
Russell Banks
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.2.1]
Mary C. Yarborough
12
Nancy Banks
[1.1.1.1.1.1.1.1.5.2.1.1]
[
=>
]
9
Thomas H. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 2 Jan 1771 d. 26 Sep 1852
9
Solomon A. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 1777 d. 1841
Christian Charity Alston
10
William Alston Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1]
Susan McNeilly
11
Mary Alston Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.1]
James Monroe Woollard
12
Susan Matilda Woollard
[1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.1]
[
=>
]
8
James Alston
[1.1.1.1.1.1.1.2]
8
William Alston
[1.1.1.1.1.1.1.3]
Charity
9
William Hinton Alston
[1.1.1.1.1.1.1.3.1]
Elizabeth Rucker
10
Ann Amanda Alston
[1.1.1.1.1.1.1.3.1.1]
Edward S. Ott
11
Anna Alston Ott
[1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1]
Augustus Holmes ALston
12
Philip Henry Alston
[1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1.1]
7
William Alston
[1.1.1.1.1.1.2]
7
James Alston
[1.1.1.1.1.1.3]
7
Joseph John Alston
[1.1.1.1.1.1.4]
7
Phillip Alston
[1.1.1.1.1.1.5]
7
Mary Alston
[1.1.1.1.1.1.6]
+
Seward
7
Elizabeth Alston
[1.1.1.1.1.1.7]
+
Williams
7
Sarah Alston
[1.1.1.1.1.1.8]
+
Kearney
7
Charity Alston
[1.1.1.1.1.1.9]
+
Dawson